Última actualización: 7 de Diciembre de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | A08127698 |
Denominación anterior | Gcp Applied Technologies Iberia SA |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Cl Antonio Machado 78-80 Ed.Australia P.2 (Viladecans). |
Objeto social | Fabricar o producir,importar,exportar,comprar,vender,distribuir,industrializar y/o comercial en cualquier otra forma compuestos sellantes,plasticos de cualquier clase,separadores de baterias,impregnadores de papel, etc. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.INDIV. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 30/11/2018 | 07/12/2018 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Gcp Applied Technologies Iberia SL.
07
Dic 2018
Con fecha 07/12/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 45415 , F 158, S 8, H B 72131, I/A 137
30
Nov 2018
Con fecha 30/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.INDIV. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45415 , F 157, S 8, H B 72131, I/A 136
06
Feb 2018
Con fecha 06/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Maraver Uroz Elias Juan |
APODERAD.SOL | Gonzalez Del Pozo Anisa |
Datos registrales: T 45415 , F 157, S 8, H B 72131, I/A 135
14
Dic 2017
DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: HENKEL IBERICA S.A.
Datos registrales: T 45415 , F 157, S 8, H B 72131, I/A 134
17
Ago 2017
Con fecha 17/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Massimo Sanita |
CONSEJERO | Lars Johan Pontus Hallengren |
PRESIDENTE | Cruz Garcia Maria Pilar |
Datos registrales: T 45415 , F 156, S 8, H B 72131, I/A 133
17
Ago 2017
Con fecha 17/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Henri Simon Magrin Benoit |
SECR.NO CONS | Espino De Balanzo Ramon |
CONSEJERO | Climent Del Olmo Sergi |
CONSEJERO | Christian Kotting |
Datos registrales: T 45415 , F 156, S 8, H B 72131, I/A 133
19
Jun 2017
Con fecha 19/06/2017, la sociedad cambia su actividad a:
FABRICAR O PRODUCIR,IMPORTAR,EXPORTAR,COMPRAR,VENDER,DISTRIBUIR,INDUSTRIALIZAR Y/O COMERCIAL EN CUALQUIER OTRA FORMA COMPUESTOS SELLANTES,PLASTICOS DE CUALQUIER CLASE,SEPARADORES DE BATERIAS,IMPREGNADORES DE PAPEL, ETC.
Datos registrales: T 45415 , F 153, S 8, H B 72131, I/A 132
19
Jun 2017
Con fecha 19/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Henri Simon Magrin Benoit |
SECR.NO CONS | Espino De Balanzo Ramon |
CONSEJERO | Climent Del Olmo Sergi |
PRESIDENTE | Christian Kotting |
Datos registrales: T 45415 , F 153, S 8, H B 72131, I/A 132
19
Jun 2017
Con fecha 19/06/2017, la sociedad pasa a denominarse GCP APPLIED TECHNOLOGIES IBERIA S.L
Datos registrales: T 45415 , F 153, S 8, H B 72131, I/A 132
19
Jun 2017
Con fecha 19/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Ruiz Peña Susana Sonia |
APODERAD.SOL | Rodriguez Torres Iria |
APODERAD.SOL | Perez Serrano Isabel |
APODERAD.SOL | Perez Masilla Delgado Patricia |
APODERAD.SOL | Mafuz Gumiel Rosa Maria |
APODERAD.SOL | Diaz Crespo Rosalia |
Datos registrales: T 45415 , F 152, S 8, H B 72131, I/A 131
09
May 2017
Con fecha 09/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45415 , F 152, S 8, H B 72131, I/A 130
15
Nov 2016
Con fecha 15/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Magrin Benoit Henri Simon |
CONSEJERO | Climent Del Olmo Sergio |
Datos registrales: T 45415 , F 152, S 8, H B 72131, I/A 129
21
Oct 2016
Con fecha 21/10/2016, la sociedad cambia su denominación social a GCP APPLIED TECHNOLOGIES IBERIA SA
Datos registrales: T 45415 , F 152, S 8, H B 72131, I/A 128
07
Sep 2016
Con fecha 07/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes cancelaciones de oficio de nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Climent Del Olmo Sergio |
CONSEJERO | Benoit Henri Simon Magrin |
Datos registrales: T 42724 , F 46, S 8, H B 72131, I/A 121 N
27
Jun 2016
Con fecha 27/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Rudolf Heinisch |
APOD.MANCOMU | Mauro Tenti |
APOD.SOL/MAN | Henri Simon Magrin Benoit |
APOD.SOL/MAN | Climent Del Olmo Sergi |
APODERAD.SOL | Christian Kotting |
Datos registrales: T 42724 , F 50, S 8, H B 72131, I/A 127
27
Jun 2016
Con fecha 27/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Russell John Leigh |
APOD.SOL/MAN | Climent Del Olmo Sergio |
Datos registrales: T 42724 , F 50, S 8, H B 72131, I/A 127
25
May 2016
Con fecha 25/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Christian Kotting |
Datos registrales: T 42724 , F 50, S 8, H B 72131, I/A 126
25
May 2016
Con fecha 25/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Russell John Leigh |
Datos registrales: T 42724 , F 50, S 8, H B 72131, I/A 126
22
Feb 2016
Con fecha 22/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Rudolf Heinisch |
APOD.SOL/MAN | Mauro Fabio Tenti |
APOD.SOL/MAN | Magrin Benoit Henri Simon |
APOD.SOL/MAN | Climent Del Olmo Sergio |
Datos registrales: T 42724 , F 49, S 8, H B 72131, I/A 125
07
Ene 2016
Con fecha 07/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42724 , F 49, S 8, H B 72131, I/A 124
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-241-08 | Barcelona | 18/12/2018 | |
BORME-A-2018-237-08 | Barcelona | 12/12/2018 | |
BORME-A-2018-32-08 | Barcelona | 14/02/2018 | |
BORME-A-2017-243-08 | Barcelona | 26/12/2017 | |
BORME-A-2017-162-08 | Barcelona | 25/08/2017 | |
BORME-A-2017-120-08 | Barcelona | 27/06/2017 | |
BORME-A-2017-92-08 | Barcelona | 18/05/2017 | |
BORME-A-2016-222-08 | Barcelona | 22/11/2016 | |
BORME-A-2016-208-08 | Barcelona | 31/10/2016 | |
BORME-A-2016-182-08 | Barcelona | 22/09/2016 | |
BORME-A-2016-126-08 | Barcelona | 04/07/2016 | |
BORME-A-2016-104-08 | Barcelona | 02/06/2016 | |
BORME-A-2016-42-08 | Barcelona | 02/03/2016 | |
BORME-A-2016-7-08 | Barcelona | 13/01/2016 | |
BORME-A-2015-239-08 | Barcelona | 16/12/2015 | |
BORME-A-2015-229-08 | Barcelona | 01/12/2015 | |
BORME-A-2015-206-08 | Barcelona | 28/10/2015 | |
BORME-A-2015-157-08 | Barcelona | 19/08/2015 | |
BORME-A-2015-119-08 | Barcelona | 26/06/2015 | |
BORME-A-2015-2-08 | Barcelona | 05/01/2015 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades