Última actualización: 10 de Octubre de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 6 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A83398586 |
Provincia | Madrid |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Rodriguez Garcia Maria Jose | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Apo.Manc. | Rius Culi Montserrat | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Apo.Manc. | Rius Culi Montserrat | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Rius Culi Montserrat | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 22/03/2016 | 10/10/2018 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 18/09/2012 | 10/10/2018 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 09/06/2017 | 10/10/2018 |
Apo.Manc. | Poitsalo Sirpa | 11/12/2017 | 10/10/2018 |
Consejero | Nuñez Arenas Villares Angel | 02/06/2017 | 10/10/2018 |
Apo.Manc. | Nuñez Arenas Villares Angel | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Apo.Manc. | Nuñez Arenas Villares Angel | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Nuñez Arenas Villares Angel | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Presidente | Myntti Tomas | 02/06/2017 | 10/10/2018 |
Con.Delegado | Myntti Tomas | 02/06/2017 | 10/10/2018 |
Consejero | Lehtinen Aku Juhani | 02/06/2017 | 10/10/2018 |
SecreNoConsj | Gil Roig Ramon | 02/06/2017 | 10/10/2018 |
Apo.Sol. | Faja Sanchez Roger | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 26/03/2018 | 10/10/2018 |
Apo.Manc. | Blanquez Martinez Manuel | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Apo.Sol. | Ayerza Izaguirre Iñaki | 07/05/2018 | 10/10/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Demag Cranes & Components SA.
10
Oct 2018
Con fecha 10/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 34342 , F 134, S 8, H M 308170, I/A 55
10
Oct 2018
CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL.
Datos registrales: T 34342 , F 134, S 8, H M 308170, I/A 55
04
Sep 2018
Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el art. 231 RRM.
Datos registrales: T 34342 , F 134, S 8, H M 308170, I/A 54m
25
Jun 2018
En fecha 25 de Junio de 2018, ha sido depositado el proyecto de fusión de las sociedades KONECRANES IBERICA SL, CIF B-60442530, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona; y la sociedad DEMAG CRANES & COMPONENTS SA, CIF A-83398586, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Datos registrales: T 17859 , F 78, S 8, H M 308170, I/A 1-M
07
May 2018
Con fecha 07/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rodriguez Garcia Maria Jose |
Apo.Manc. | Rius Culi Montserrat |
Apo.Manc. | Nuñez Arenas Villares Angel |
Apo.Sol. | Faja Sanchez Roger |
Apo.Manc. | Blanquez Martinez Manuel |
Apo.Sol. | Ayerza Izaguirre Iñaki |
Datos registrales: T 34342 , F 132, S 8, H M 308170, I/A 54
07
May 2018
Con fecha 07/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rodriguez Garcia Maria Jose |
Apo.Man.Soli | Melli Ortega Rodrigo |
Apo.Man.Soli | Martinez Bernardo Felix Mariano |
Apo.Man.Soli | Grand Nicolas Bruno Daniel |
Apo.Man.Soli | Garcia Costales David |
Apoderado | Cañibano Ramos Alfredo |
Apo.Man.Soli | Bennett Mark |
Datos registrales: T 34342 , F 132, S 8, H M 308170, I/A 54
26
Mar 2018
Con fecha 26/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 34342 , F 132, S 8, H M 308170, I/A 53
11
Dic 2017
Con fecha 11/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Bradley Kevin Patrick |
Datos registrales: T 34342 , F 132, S 8, H M 308170, I/A 52
11
Dic 2017
Con fecha 11/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Poitsalo Sirpa |
Apo.Manc. | Ottola Teo Juhani |
Datos registrales: T 34342 , F 131, S 8, H M 308170, I/A 51
13
Jun 2017
Con fecha 13/06/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias KONECRANES IBERICA SLU.
Datos registrales: T 34342 , F 131, S 8, H M 308170, I/A 50
09
Jun 2017
Con fecha 09/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 34342 , F 130, S 8, H M 308170, I/A 49
02
Jun 2017
Con fecha 02/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Nuñez Arenas Villares Angel |
Consejero | Myntti Tomas |
Consejero | Lehtinen Aku Juhani |
SecreNoConsj | Gil Roig Ramon |
Datos registrales: T 34342 , F 130, S 8, H M 308170, I/A 48
02
Jun 2017
Con fecha 02/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Smith Graham John |
Apoderado | Filipov Stoyan |
Apo.Man.Soli | Cohen Eric I |
Apo.Manc. | Bradley Kevin Patrick |
Datos registrales: T 34342 , F 130, S 8, H M 308170, I/A 48
02
Jun 2017
Con fecha 02/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Filipov Stoyan |
Consejero | Cohen Eric I |
Consejero | Bradley Kevin Patrick |
SecreNoConsj | Belzuz Fernandez Enrique |
Datos registrales: T 34342 , F 130, S 8, H M 308170, I/A 48
13
Abr 2016
Con fecha 13/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Mata Montes Ignacio |
Apoderado | Llagostera Wieler Esteban |
Apoderado | Leopold Bernd |
Apoderado | Diaz Trujillo Fernando |
Apoderado | De Arcos Perez Gemma |
Datos registrales: T 34342 , F 129, S 8, H M 308170, I/A 47
22
Mar 2016
Con fecha 22/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 34342 , F 129, S 8, H M 308170, I/A 46
29
Feb 2016
Con fecha 29/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rodetis Gregory Alexander |
Datos registrales: T 34342 , F 129, S 8, H M 308170, I/A 45
15
Feb 2016
Con fecha 15/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Bennett Mark |
Datos registrales: T 34342 , F 128, S 8, H M 308170, I/A 44
13
Ago 2015
Con fecha 13/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Smith Graham John |
Apoderado | Rodetis Gregory Alexander |
Datos registrales: T 32018 , F 25, S 8, H M 308170, I/A 42
13
Ago 2015
Con fecha 13/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Galichon Jean Pierre |
Datos registrales: T 32018 , F 25, S 8, H M 308170, I/A 42
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-201-28 | Madrid | 18/10/2018 | |
BORME-A-2018-177-28 | Madrid | 13/09/2018 | |
BORME-A-2018-125-28 | Madrid | 02/07/2018 | |
BORME-A-2018-91-28 | Madrid | 14/05/2018 | |
BORME-A-2018-67-28 | Madrid | 06/04/2018 | |
BORME-A-2017-239-28 | Madrid | 19/12/2017 | |
BORME-A-2017-238-28 | Madrid | 18/12/2017 | |
BORME-A-2017-115-28 | Madrid | 20/06/2017 | |
BORME-A-2017-114-28 | Madrid | 19/06/2017 | |
BORME-A-2017-109-28 | Madrid | 12/06/2017 | |
BORME-A-2016-77-28 | Madrid | 22/04/2016 | |
BORME-A-2016-62-28 | Madrid | 01/04/2016 | |
BORME-A-2016-46-28 | Madrid | 08/03/2016 | |
BORME-A-2016-35-28 | Madrid | 22/02/2016 | |
BORME-A-2015-159-28 | Madrid | 21/08/2015 | |
BORME-A-2015-64-28 | Madrid | 07/04/2015 | |
BORME-A-2015-24-28 | Madrid | 05/02/2015 | |
BORME-A-2014-136-28 | Madrid | 21/07/2014 | |
BORME-A-2014-108-28 | Madrid | 10/06/2014 | |
BORME-A-2014-46-28 | Madrid | 07/03/2014 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades